Name: | FLEXIBLE FABRICATORS, INC. |
Jurisdiction: | New York |
Legal type: | DOMESTIC BUSINESS CORPORATION |
Status: | Inactive |
Date of registration: | 19 May 1986 (39 years ago) |
Date of dissolution: | 02 Jul 1997 |
Entity Number: | 1083781 |
ZIP code: | 11208 |
County: | Kings |
Place of Formation: | New York |
Address: | 883 ELTON STREET, BROOKLYN, NY, United States, 11208 |
Principal Address: | 55 JERSEY AVENUE, PORT JERVIS, NY, United States, 12771 |
Shares Details
Shares issued 200
Share Par Value 0
Type NO PAR VALUE
Name | Role | Address |
---|---|---|
ALLAN J. RODOLITZ | Chief Executive Officer | 883 ELTON PLACE, BROOKLYN, NY, United States, 11208 |
Name | Role | Address |
---|---|---|
THE CORPORATION | DOS Process Agent | 883 ELTON STREET, BROOKLYN, NY, United States, 11208 |
Start date | End date | Type | Value |
---|---|---|---|
1986-05-19 | 1992-12-07 | Address | 6 EAST 39TH STREET, NEW YORK, NY, 10016, USA (Type of address: Service of Process) |
Filing Number | Date Filed | Type | Effective Date |
---|---|---|---|
970702000026 | 1997-07-02 | CERTIFICATE OF DISSOLUTION | 1997-07-02 |
960528002620 | 1996-05-28 | BIENNIAL STATEMENT | 1996-05-01 |
930806002090 | 1993-08-06 | BIENNIAL STATEMENT | 1993-05-01 |
921207003223 | 1992-12-07 | BIENNIAL STATEMENT | 1992-05-01 |
B385154-3 | 1986-07-28 | CERTIFICATE OF AMENDMENT | 1986-07-28 |
B360607-4 | 1986-05-19 | CERTIFICATE OF INCORPORATION | 1986-05-19 |
Inspection Nr | Report ID | Date Opened | Site Address | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109052415 | 0213100 | 1996-06-04 | 55 JERSEY AVE., PORT JERVIS, NY, 12771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2254795 | 0213100 | 1985-07-11 | JERSEY AVENUE, PORT JERVIS, NY, 12771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12096095 | 0235500 | 1975-10-09 | 55 JERSEY AVE, Port Jervis, NY, 12771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12095949 | 0235500 | 1975-08-25 | 55 JERSEY AVE, Port Jervis, NY, 12771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Citation ID | 01001 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100212 A03 II |
Issuance Date | 1975-09-18 |
Abatement Due Date | 1975-10-03 |
Current Penalty | 30.0 |
Initial Penalty | 30.0 |
Nr Instances | 3 |
Citation ID | 01002 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100212 A01 |
Issuance Date | 1975-09-18 |
Abatement Due Date | 1975-10-03 |
Current Penalty | 25.0 |
Initial Penalty | 25.0 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 01003 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100213 I01 |
Issuance Date | 1975-09-18 |
Abatement Due Date | 1975-10-03 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 01004 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100309 A 025045 |
Issuance Date | 1975-09-18 |
Abatement Due Date | 1975-10-03 |
Nr Instances | 2 |
Citation ID | 01005 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100219 E03 I |
Issuance Date | 1975-09-18 |
Abatement Due Date | 1975-10-03 |
Current Penalty | 35.0 |
Initial Penalty | 35.0 |
Nr Instances | 8 |
Citation ID | 01006 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100252 A02 IVC |
Issuance Date | 1975-09-18 |
Abatement Due Date | 1975-10-03 |
Initial Penalty | 40.0 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 01007 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100213 C01 |
Issuance Date | 1975-09-18 |
Abatement Due Date | 1975-10-03 |
Initial Penalty | 35.0 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 01008 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100213 C02 |
Issuance Date | 1975-09-18 |
Abatement Due Date | 1975-10-03 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 01009 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100213 C03 |
Issuance Date | 1975-09-18 |
Abatement Due Date | 1975-10-03 |
Nr Instances | 1 |
Date of last update: 16 Mar 2025
Sources: New York Secretary of State