Name: | A. & Z. PLASTIC PRODUCTS CO., INC. |
Jurisdiction: | New York |
Legal type: | DOMESTIC BUSINESS CORPORATION |
Status: | Inactive |
Date of registration: | 22 Jan 1959 (66 years ago) |
Date of dissolution: | 16 May 1995 |
Entity Number: | 116619 |
ZIP code: | 10007 |
County: | Bronx |
Place of Formation: | New York |
Address: | 277 BROADWAY, NEW YORK, NY, United States, 10007 |
Shares Details
Shares issued 200
Share Par Value 0
Type NO PAR VALUE
Name | Role | Address |
---|---|---|
JOSEPH G. KAPLAN | DOS Process Agent | 277 BROADWAY, NEW YORK, NY, United States, 10007 |
Filing Number | Date Filed | Type | Effective Date |
---|---|---|---|
C275383-2 | 1999-06-21 | ASSUMED NAME CORP INITIAL FILING | 1999-06-21 |
950516000602 | 1995-05-16 | CERTIFICATE OF DISSOLUTION | 1995-05-16 |
142977 | 1959-01-22 | CERTIFICATE OF INCORPORATION | 1959-01-22 |
Inspection Nr | Report ID | Date Opened | Site Address | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12092847 | 0235500 | 1978-06-29 | 4443 THIRD AVENUE, New York -Richmond, NY, 10457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12092268 | 0235500 | 1978-02-09 | 4443 THIRD AVENUE, New York -Richmond, NY, 10457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12092003 | 0235500 | 1977-11-07 | 4443 THIRD AVENUE, New York -Richmond, NY, 10457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Citation ID | 01001 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100212 A03 II |
Issuance Date | 1977-12-14 |
Abatement Due Date | 1978-04-03 |
Current Penalty | 240.0 |
Initial Penalty | 240.0 |
Nr Instances | 10 |
Citation ID | 02001 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100022 A03 |
Issuance Date | 1977-12-14 |
Abatement Due Date | 1978-01-20 |
Nr Instances | 4 |
Citation ID | 02002 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100025 D01 X |
Issuance Date | 1977-11-17 |
Abatement Due Date | 1977-11-28 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 02003 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100212 A01 |
Issuance Date | 1977-12-14 |
Abatement Due Date | 1978-04-03 |
Nr Instances | 3 |
Citation ID | 02004 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100212 B |
Issuance Date | 1977-11-17 |
Abatement Due Date | 1977-11-28 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 02005 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100215 A02 |
Issuance Date | 1977-12-14 |
Abatement Due Date | 1978-01-20 |
Nr Instances | 2 |
Citation ID | 02006 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100219 D01 |
Issuance Date | 1977-12-14 |
Abatement Due Date | 1978-04-03 |
Nr Instances | 3 |
Citation ID | 02007 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100219 F03 |
Issuance Date | 1977-12-14 |
Abatement Due Date | 1978-04-03 |
Nr Instances | 3 |
Citation ID | 02008 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100309 A 011017 |
Issuance Date | 1977-12-14 |
Abatement Due Date | 1978-04-03 |
Nr Instances | 3 |
Citation ID | 02009 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100309 A 025045 |
Issuance Date | 1977-12-14 |
Abatement Due Date | 1978-04-03 |
Nr Instances | 9 |
Date of last update: 18 Mar 2025
Sources: New York Secretary of State