Name: | MORANDO MACHINE WORKS, INC. |
Jurisdiction: | New York |
Legal type: | DOMESTIC BUSINESS CORPORATION |
Status: | Inactive |
Date of registration: | 25 May 1961 (64 years ago) |
Date of dissolution: | 23 Sep 1998 |
Entity Number: | 138227 |
ZIP code: | 10475 |
County: | Bronx |
Place of Formation: | New York |
Address: | 2224 HOLLERS AVE., BRONX, NY, United States, 10475 |
Shares Details
Shares issued 200
Share Par Value 0
Type NO PAR VALUE
Name | Role | Address |
---|---|---|
MORANDO MACHINE WORKS, INC. | DOS Process Agent | 2224 HOLLERS AVE., BRONX, NY, United States, 10475 |
Filing Number | Date Filed | Type | Effective Date |
---|---|---|---|
DP-1389474 | 1998-09-23 | DISSOLUTION BY PROCLAMATION | 1998-09-23 |
B653207-2 | 1988-06-17 | ASSUMED NAME CORP INITIAL FILING | 1988-06-17 |
270814 | 1961-05-25 | CERTIFICATE OF INCORPORATION | 1961-05-25 |
Inspection Nr | Report ID | Date Opened | Site Address | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12119954 | 0235500 | 1978-04-11 | RTE 6, Mahopac, NY, 10541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12125324 | 0235500 | 1977-01-19 | ROUTE 6, New York -Richmond, NY, 10541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12103438 | 0235500 | 1976-11-30 | ROUTE 6, Carmel, NY, 10541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Citation ID | 01001 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100037 D01 |
Issuance Date | 1976-12-03 |
Abatement Due Date | 1976-12-07 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 01002 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100219 E03 I |
Issuance Date | 1976-12-03 |
Abatement Due Date | 1976-12-14 |
Nr Instances | 4 |
Citation ID | 01003 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100213 C01 |
Issuance Date | 1976-12-03 |
Abatement Due Date | 1976-12-23 |
Nr Instances | 2 |
Citation ID | 01004 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100213 C02 |
Issuance Date | 1976-12-03 |
Abatement Due Date | 1976-12-23 |
Nr Instances | 2 |
Citation ID | 01005 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100213 C03 |
Issuance Date | 1976-12-03 |
Abatement Due Date | 1976-12-23 |
Nr Instances | 2 |
Citation ID | 01006 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100157 D03 I |
Issuance Date | 1976-12-03 |
Abatement Due Date | 1976-12-14 |
Nr Instances | 3 |
Citation ID | 01007 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100022 A01 |
Issuance Date | 1976-12-03 |
Abatement Due Date | 1977-01-04 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 01008 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100215 A02 |
Issuance Date | 1976-12-03 |
Abatement Due Date | 1976-12-23 |
Nr Instances | 1 |
Date of last update: 18 Mar 2025
Sources: New York Secretary of State