Name: | ATLANTIC ROLL FORMING CORP. |
Jurisdiction: | New York |
Legal type: | DOMESTIC BUSINESS CORPORATION |
Status: | Inactive |
Date of registration: | 24 Jul 1961 (64 years ago) |
Date of dissolution: | 25 Sep 1991 |
Entity Number: | 139805 |
County: | Queens |
Place of Formation: | New York |
Address: | 59-44 60TH RD., QUEENS, NY, United States |
Shares Details
Shares issued 200
Share Par Value 0
Type NO PAR VALUE
Name | Role | Address |
---|---|---|
ATLANTIC ROLL FORMING CORP. | DOS Process Agent | 59-44 60TH RD., QUEENS, NY, United States |
Filing Number | Date Filed | Type | Effective Date |
---|---|---|---|
DP-550517 | 1991-09-25 | DISSOLUTION BY PROCLAMATION | 1991-09-25 |
B737926-2 | 1989-02-06 | ASSUMED NAME CORP INITIAL FILING | 1989-02-06 |
279853 | 1961-07-24 | CERTIFICATE OF INCORPORATION | 1961-07-24 |
Inspection Nr | Report ID | Date Opened | Site Address | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11848298 | 0215600 | 1978-03-06 | 50-05 98TH ST, New York -Richmond, NY, 11368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11881794 | 0215600 | 1978-02-02 | 50-05 95 STREET, New York -Richmond, NY, 11368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11881513 | 0215600 | 1977-10-07 | 50-05 98 STREET, New York -Richmond, NY, 11368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11881166 | 0215600 | 1977-07-20 | 50 05 98 STREET, NY, 11368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11880960 | 0215600 | 1977-05-24 | 50 05 98 STREET, NY, 11368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Citation ID | 01001 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100212 A01 |
Issuance Date | 1977-06-09 |
Abatement Due Date | 1978-01-31 |
Current Penalty | 60.0 |
Initial Penalty | 60.0 |
Contest Date | 1977-06-15 |
Nr Instances | 4 |
Citation ID | 01002 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100217 B08 III |
Issuance Date | 1977-06-09 |
Abatement Due Date | 1978-03-02 |
Current Penalty | 60.0 |
Initial Penalty | 60.0 |
Contest Date | 1977-06-15 |
Nr Instances | 2 |
Citation ID | 01003 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100217 C01 I |
Issuance Date | 1977-06-09 |
Abatement Due Date | 1978-03-02 |
Current Penalty | 60.0 |
Initial Penalty | 60.0 |
Contest Date | 1977-06-15 |
Nr Instances | 6 |
Citation ID | 02001 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100217 E01 I |
Issuance Date | 1977-05-27 |
Abatement Due Date | 1977-06-27 |
Nr Instances | 2 |
Date of last update: 18 Mar 2025
Sources: New York Secretary of State