Name: | FRANK P. SCHMITT & CO. INC. |
Jurisdiction: | New York |
Legal type: | DOMESTIC BUSINESS CORPORATION |
Status: | Inactive |
Date of registration: | 30 Mar 1964 (61 years ago) |
Date of dissolution: | 25 Sep 1991 |
Entity Number: | 175111 |
ZIP code: | 10013 |
County: | Kings |
Place of Formation: | New York |
Address: | 401 BROADWAY, NEW YORK, NY, United States, 10013 |
Shares Details
Shares issued 200
Share Par Value 0
Type NO PAR VALUE
Name | Role | Address |
---|---|---|
% FINKEL & NADLER | DOS Process Agent | 401 BROADWAY, NEW YORK, NY, United States, 10013 |
Filing Number | Date Filed | Type | Effective Date |
---|---|---|---|
C203978-2 | 1993-10-18 | ASSUMED NAME CORP INITIAL FILING | 1993-10-18 |
DP-583875 | 1991-09-25 | DISSOLUTION BY PROCLAMATION | 1991-09-25 |
428737 | 1964-03-30 | CERTIFICATE OF INCORPORATION | 1964-03-30 |
Inspection Nr | Report ID | Date Opened | Site Address | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11702453 | 0235300 | 1976-07-01 | 808 FLUSHING AVENUE, New York -Richmond, NY, 11206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11701398 | 0235300 | 1975-11-07 | 808 FLUSHING AVENUE, New York -Richmond, NY, 11206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11680220 | 0235300 | 1975-09-16 | 808 FLUSHING AVENUE, New York -Richmond, NY, 11206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Citation ID | 01001 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19030002 A |
Issuance Date | 1975-09-26 |
Abatement Due Date | 1975-10-06 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 01002 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100212 A05 |
Issuance Date | 1975-09-26 |
Abatement Due Date | 1975-10-06 |
Current Penalty | 25.0 |
Initial Penalty | 25.0 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 01003 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100213 D01 |
Issuance Date | 1975-09-26 |
Abatement Due Date | 1975-10-06 |
Current Penalty | 40.0 |
Initial Penalty | 40.0 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 01004 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100213 D02 |
Issuance Date | 1975-09-26 |
Abatement Due Date | 1975-10-06 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 01005 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100219 E03 I |
Issuance Date | 1975-09-26 |
Abatement Due Date | 1975-10-06 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 01006 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100219 C04 I |
Issuance Date | 1975-09-26 |
Abatement Due Date | 1975-10-06 |
Nr Instances | 3 |
Citation ID | 01007 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100252 A02 IID |
Issuance Date | 1975-09-26 |
Abatement Due Date | 1975-10-06 |
Current Penalty | 30.0 |
Initial Penalty | 30.0 |
Nr Instances | 2 |
Citation ID | 01008 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100252 A02 IVC |
Issuance Date | 1975-09-26 |
Abatement Due Date | 1975-10-06 |
Nr Instances | 2 |
Citation ID | 01009 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100025 D01 X |
Issuance Date | 1975-09-26 |
Abatement Due Date | 1975-10-06 |
Current Penalty | 25.0 |
Initial Penalty | 25.0 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 01010 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100213 G01 |
Issuance Date | 1975-09-26 |
Abatement Due Date | 1975-10-06 |
Current Penalty | 35.0 |
Initial Penalty | 35.0 |
Contest Date | 1975-12-15 |
Final Order | 1976-07-15 |
Nr Instances | 1 |
FTA Issuance Date | 1975-10-06 |
FTA Current Penalty | 250.0 |
Citation ID | 01011 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100213 G03 |
Issuance Date | 1975-09-26 |
Abatement Due Date | 1975-10-06 |
Nr Instances | 1 |
Date of last update: 18 Mar 2025
Sources: New York Secretary of State