Name: | WIEDMAN & SON WIRE PRODUCTS, INC. |
Jurisdiction: | New York |
Legal type: | DOMESTIC BUSINESS CORPORATION |
Status: | Inactive |
Date of registration: | 05 Oct 1964 (61 years ago) |
Date of dissolution: | 27 Jun 2001 |
Entity Number: | 180294 |
ZIP code: | 10036 |
County: | New York |
Place of Formation: | New York |
Address: | 19 W. 44TH ST., NEW YORK, NY, United States, 10036 |
Shares Details
Shares issued 200
Share Par Value 0
Type NO PAR VALUE
Name | Role | Address |
---|---|---|
% SIDNEY DIAMOND | DOS Process Agent | 19 W. 44TH ST., NEW YORK, NY, United States, 10036 |
Filing Number | Date Filed | Type | Effective Date |
---|---|---|---|
C332070-2 | 2003-05-30 | ASSUMED NAME CORP INITIAL FILING | 2003-05-30 |
DP-1568926 | 2001-06-27 | DISSOLUTION BY PROCLAMATION | 2001-06-27 |
457780 | 1964-10-05 | CERTIFICATE OF INCORPORATION | 1964-10-05 |
Inspection Nr | Report ID | Date Opened | Site Address | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1730662 | 0215000 | 1984-10-04 | 142-146 W 14TH ST, NEW YORK, NY, 10014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11768470 | 0215000 | 1982-01-05 | 142 WEST 14 STREET, New York -Richmond, NY, 10011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11714490 | 0215000 | 1977-04-18 | 142 W 14 ST, New York -Richmond, NY, 10011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11714193 | 0215000 | 1977-03-11 | 142 W 14ST, New York -Richmond, NY, 10011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Citation ID | 01001 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100217 C02 IA |
Issuance Date | 1977-03-18 |
Abatement Due Date | 1977-04-15 |
Current Penalty | 400.0 |
Initial Penalty | 400.0 |
Nr Instances | 9 |
Citation ID | 02001 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100219 E03 I |
Issuance Date | 1977-03-18 |
Abatement Due Date | 1977-03-21 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 02002 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100309 A 025045 |
Issuance Date | 1977-03-18 |
Abatement Due Date | 1977-04-08 |
Nr Instances | 2 |
Citation ID | 02003 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100217 B04 I |
Issuance Date | 1977-03-18 |
Abatement Due Date | 1977-04-08 |
Nr Instances | 2 |
Citation ID | 02004 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100157 D03 I |
Issuance Date | 1977-03-18 |
Abatement Due Date | 1977-04-08 |
Nr Instances | 3 |
Date of last update: 18 Mar 2025
Sources: New York Secretary of State