Name: | MACK PALLETT & LUMBER CO., INC. |
Jurisdiction: | New York |
Legal type: | DOMESTIC BUSINESS CORPORATION |
Status: | Inactive |
Date of registration: | 03 Mar 1967 (58 years ago) |
Date of dissolution: | 27 Jun 2001 |
Entity Number: | 207592 |
ZIP code: | 14217 |
County: | Erie |
Place of Formation: | New York |
Address: | TIMOTHY MACK, P.O. BOX 28 1803 ELMWOOD AVE, KENMORE, NY, United States, 14217 |
Shares Details
Shares issued 200
Share Par Value 0
Type NO PAR VALUE
Name | Role | Address |
---|---|---|
THE CORPORATION | DOS Process Agent | TIMOTHY MACK, P.O. BOX 28 1803 ELMWOOD AVE, KENMORE, NY, United States, 14217 |
Name | Role | Address |
---|---|---|
TIMOTHY MACK | Chief Executive Officer | P.O. BOX 28, 1803 ELMWOOD AVENUE, KENMORE, NY, United States, 14217 |
Start date | End date | Type | Value |
---|---|---|---|
1967-03-03 | 1995-04-12 | Address | 170 FRANKLIN ST., 705 CROSBY BLDG, BUFFALO, NY, 14202, USA (Type of address: Service of Process) |
Filing Number | Date Filed | Type | Effective Date |
---|---|---|---|
20080507006 | 2008-05-07 | ASSUMED NAME CORP DISCONTINUANCE | 2008-05-07 |
DP-1550780 | 2001-06-27 | DISSOLUTION BY PROCLAMATION | 2001-06-27 |
C299689-2 | 2001-03-08 | ASSUMED NAME CORP INITIAL FILING | 2001-03-08 |
970408002479 | 1997-04-08 | BIENNIAL STATEMENT | 1997-03-01 |
950412002089 | 1995-04-12 | BIENNIAL STATEMENT | 1994-03-01 |
606390-6 | 1967-03-03 | CERTIFICATE OF INCORPORATION | 1967-03-03 |
Inspection Nr | Report ID | Date Opened | Site Address | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10854057 | 0213600 | 1977-03-02 | 275 MAYVILLE ROAD, Kenmore, NY, 14217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10801900 | 0213600 | 1976-10-21 | 275 MAYVILLE ROAD, Kenmore, NY, 14217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10824449 | 0213600 | 1976-09-14 | 275 MAYVILLE ROAD, Kenmore, NY, 14217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10824431 | 0213600 | 1976-09-01 | 275 MAYVILLE ROAD, Kenmore, NY, 14217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10824399 | 0213600 | 1976-08-12 | 275 MAYVILLE ROAD, Kenmore, NY, 14217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Citation ID | 01001A |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100213 H01 |
Issuance Date | 1976-08-18 |
Abatement Due Date | 1977-03-01 |
Current Penalty | 500.0 |
Initial Penalty | 500.0 |
Nr Instances | 2 |
Citation ID | 01001B |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100213 H04 |
Issuance Date | 1976-08-18 |
Abatement Due Date | 1976-10-19 |
Nr Instances | 2 |
Citation ID | 01001C |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100213 H01 |
Issuance Date | 1976-08-18 |
Abatement Due Date | 1976-10-19 |
Nr Instances | 2 |
Citation ID | 02001 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100213 I01 |
Issuance Date | 1976-08-18 |
Abatement Due Date | 1976-09-09 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 02002 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100219 E01 I |
Issuance Date | 1976-08-18 |
Abatement Due Date | 1976-09-09 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 02003 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19030002 A01 |
Issuance Date | 1976-08-18 |
Abatement Due Date | 1976-09-09 |
Current Penalty | 25.0 |
Initial Penalty | 25.0 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 02004 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19040002 A |
Issuance Date | 1976-08-18 |
Abatement Due Date | 1976-09-09 |
Current Penalty | 10.0 |
Initial Penalty | 10.0 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 02005 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19040005 A |
Issuance Date | 1976-08-18 |
Abatement Due Date | 1976-09-09 |
Current Penalty | 10.0 |
Initial Penalty | 10.0 |
Nr Instances | 1 |
Date of last update: 18 Mar 2025
Sources: New York Secretary of State