Name: | THE FLORENTINE CRAFTSMEN, INC. |
Jurisdiction: | New York |
Legal type: | DOMESTIC BUSINESS CORPORATION |
Status: | Inactive |
Date of registration: | 31 Mar 1926 (99 years ago) |
Date of dissolution: | 24 Mar 2011 |
Entity Number: | 22116 |
ZIP code: | 10010 |
County: | New York |
Place of Formation: | New York |
Address: | 45 E. 22 ST., NEW YORK, NY, United States, 10010 |
Shares Details
Shares issued 0
Share Par Value 50000
Type CAP
Name | Role | Address |
---|---|---|
THE FLORENTINE CRAFTSMEN, INC. | DOS Process Agent | 45 E. 22 ST., NEW YORK, NY, United States, 10010 |
Filing Number | Date Filed | Type | Effective Date |
---|---|---|---|
110324000808 | 2011-03-24 | CERTIFICATE OF DISSOLUTION | 2011-03-24 |
C354446-3 | 2004-10-22 | ASSUMED NAME CORP INITIAL FILING | 2004-10-22 |
DES17856 | 1934-12-17 | CERTIFICATE OF AMENDMENT | 1934-12-17 |
2778-67 | 1926-03-31 | CERTIFICATE OF INCORPORATION | 1926-03-31 |
Inspection Nr | Report ID | Date Opened | Site Address | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100182625 | 0215600 | 1986-05-05 | 46-24 28TH STREET, LONG ISLAND CITY, NY, 11101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11740396 | 0215000 | 1976-12-14 | 654 FIRST AVENUE, New York -Richmond, NY, 10016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11724069 | 0215000 | 1976-09-14 | 654 1ST AVENUE, New York -Richmond, NY, 10016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Citation ID | 01001 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19030002 A01 |
Issuance Date | 1976-09-16 |
Abatement Due Date | 1976-09-27 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 01002 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19040002 A |
Issuance Date | 1976-09-16 |
Abatement Due Date | 1976-09-27 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 01003 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19040005 A |
Issuance Date | 1976-09-16 |
Abatement Due Date | 1976-09-27 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 01004 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100030 A02 |
Issuance Date | 1976-09-16 |
Abatement Due Date | 1976-10-02 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 01005 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100212 A05 |
Issuance Date | 1976-09-16 |
Abatement Due Date | 1976-09-22 |
Current Penalty | 25.0 |
Initial Penalty | 25.0 |
Nr Instances | 3 |
Citation ID | 01006 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100215 A04 |
Issuance Date | 1976-09-16 |
Abatement Due Date | 1976-09-22 |
Current Penalty | 25.0 |
Initial Penalty | 25.0 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 01007 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100215 B09 |
Issuance Date | 1976-09-16 |
Abatement Due Date | 1976-09-22 |
Current Penalty | 25.0 |
Initial Penalty | 25.0 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 01008 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100309 A 025045 |
Issuance Date | 1976-09-16 |
Abatement Due Date | 1976-09-22 |
Current Penalty | 30.0 |
Initial Penalty | 30.0 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 01009 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100252 A02 IVC |
Issuance Date | 1976-09-16 |
Abatement Due Date | 1976-09-20 |
Current Penalty | 35.0 |
Initial Penalty | 35.0 |
Nr Instances | 1 |
Date of last update: 19 Mar 2025
Sources: New York Secretary of State