Name: | TIFFANY PLASTIC MOLDERS, INC. |
Jurisdiction: | New York |
Legal type: | DOMESTIC BUSINESS CORPORATION |
Status: | Inactive |
Date of registration: | 23 Jun 1971 (54 years ago) |
Date of dissolution: | 24 Dec 1991 |
Entity Number: | 309920 |
ZIP code: | 10038 |
County: | New York |
Place of Formation: | New York |
Address: | 170 BROADWAY, NEW YORK, NY, United States, 10038 |
Shares Details
Shares issued 200
Share Par Value 0
Type NO PAR VALUE
Name | Role | Address |
---|---|---|
MARTIN J. WEISSMAN | DOS Process Agent | 170 BROADWAY, NEW YORK, NY, United States, 10038 |
Filing Number | Date Filed | Type | Effective Date |
---|---|---|---|
20201211048 | 2020-12-11 | ASSUMED NAME LLC DISCONTINUANCE | 2020-12-11 |
20191231008 | 2019-12-31 | ASSUMED NAME LLC INITIAL FILING | 2019-12-31 |
DP-635170 | 1991-12-24 | DISSOLUTION BY PROCLAMATION | 1991-12-24 |
916234-4 | 1971-06-23 | CERTIFICATE OF INCORPORATION | 1971-06-23 |
Inspection Nr | Report ID | Date Opened | Site Address | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12067872 | 0235500 | 1979-07-19 | 403 CONCORD AVENUE, New York -Richmond, NY, 10454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12093555 | 0235500 | 1979-04-04 | 403 CONCORD AVENUE, New York -Richmond, NY, 10454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12093175 | 0235500 | 1978-09-21 | 403 CONCORD AVENUE, New York -Richmond, NY, 10454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12067351 | 0235500 | 1978-07-06 | 403 CONCORD AVENUE, New York -Richmond, NY, 10454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12067294 | 0235500 | 1978-04-21 | 443 CONCORD AVENUE, New York -Richmond, NY, 10454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Citation ID | 01001 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100095 B01 |
Issuance Date | 1978-05-31 |
Abatement Due Date | 1979-05-15 |
Current Penalty | 300.0 |
Initial Penalty | 450.0 |
Contest Date | 1978-06-15 |
Nr Instances | 2 |
Inspection Type | Planned |
Scope | Complete |
Safety/Health | Safety |
Close Conference | 1978-04-05 |
Case Closed | 1979-04-18 |
Violation Items
Citation ID | 01001 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100212 A03 II |
Issuance Date | 1978-04-18 |
Abatement Due Date | 1978-07-19 |
Current Penalty | 75.0 |
Initial Penalty | 150.0 |
Contest Date | 1978-05-15 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 02001 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100022 A03 |
Issuance Date | 1978-04-18 |
Abatement Due Date | 1978-07-19 |
Contest Date | 1978-05-15 |
Nr Instances | 2 |
Citation ID | 02002 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100022 B02 |
Issuance Date | 1978-04-18 |
Abatement Due Date | 1978-05-11 |
Contest Date | 1978-05-15 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 02003 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100036 B04 |
Issuance Date | 1978-04-18 |
Abatement Due Date | 1978-05-19 |
Contest Date | 1978-05-15 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 02004 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100106 E02 IIB2 |
Issuance Date | 1978-04-18 |
Abatement Due Date | 1978-05-19 |
Contest Date | 1978-05-15 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 02005 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100309 A 011017 |
Issuance Date | 1978-04-18 |
Abatement Due Date | 1978-04-27 |
Contest Date | 1978-05-15 |
Nr Instances | 2 |
Citation ID | 02006 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100309 A 025045 |
Issuance Date | 1978-04-18 |
Abatement Due Date | 1978-05-04 |
Contest Date | 1978-05-15 |
Nr Instances | 2 |
Date of last update: 18 Mar 2025
Sources: New York Secretary of State