Name: | LAKE ERIE TECHNOLOGY, INC. |
Jurisdiction: | New York |
Legal type: | DOMESTIC BUSINESS CORPORATION |
Status: | Inactive |
Date of registration: | 10 Sep 1976 (49 years ago) |
Date of dissolution: | 25 Mar 1992 |
Entity Number: | 409527 |
ZIP code: | 14165 |
County: | Erie |
Place of Formation: | New York |
Address: | 11145 BROADWAY, BUFFALO, NY, United States, 14165 |
Shares Details
Shares issued 4000
Share Par Value 25
Type PAR VALUE
Name | Role | Address |
---|---|---|
LAKE ERIE TECHNOLOGY, INC. | DOS Process Agent | 11145 BROADWAY, BUFFALO, NY, United States, 14165 |
Start date | End date | Type | Value |
---|---|---|---|
1976-09-10 | 1978-09-26 | Shares | Share type: PAR VALUE, Number of shares: 1000, Par value: 25 |
1976-09-10 | 1982-02-04 | Address | 210 FRENCH RD., BUFFALO, NY, 14227, USA (Type of address: Service of Process) |
Filing Number | Date Filed | Type | Effective Date |
---|---|---|---|
20100722022 | 2010-07-22 | ASSUMED NAME CORP INITIAL FILING | 2010-07-22 |
DP-663117 | 1992-03-25 | DISSOLUTION BY PROCLAMATION | 1992-03-25 |
A838384-3 | 1982-02-04 | CERTIFICATE OF AMENDMENT | 1982-02-04 |
A518383-3 | 1978-09-26 | CERTIFICATE OF AMENDMENT | 1978-09-26 |
A341488-5 | 1976-09-10 | CERTIFICATE OF INCORPORATION | 1976-09-10 |
Inspection Nr | Report ID | Date Opened | Site Address | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10833168 | 0213600 | 1982-08-23 | P1145 BROADWAY, Alden, NY, 14165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10826337 | 0213600 | 1979-05-25 | 210 FRENCH ROAD, Cheektowaga, NY, 14227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10826329 | 0213600 | 1979-05-15 | 210 FRENCH ROAD, Cheektowaga, NY, 14227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10826253 | 0213600 | 1979-04-18 | 210 FRENCH ROAD, Cheektowaga, NY, 14227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Type | Complaint |
Activity Nr | 320203003 |
Violation Items
Citation ID | 01001 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100212 A03 II |
Issuance Date | 1979-05-07 |
Abatement Due Date | 1979-05-10 |
Current Penalty | 105.0 |
Initial Penalty | 210.0 |
Contest Date | 1979-06-15 |
Final Order | 1979-10-15 |
Nr Instances | 1 |
Related Event Code (REC) | Complaint |
Citation ID | 01002 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100219 E03 I |
Issuance Date | 1979-05-07 |
Abatement Due Date | 1979-05-24 |
Current Penalty | 60.0 |
Initial Penalty | 120.0 |
Contest Date | 1979-06-15 |
Final Order | 1979-10-15 |
Nr Instances | 4 |
Related Event Code (REC) | Complaint |
Citation ID | 02001 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100215 A04 |
Issuance Date | 1979-05-07 |
Abatement Due Date | 1979-05-10 |
Contest Date | 1979-06-15 |
Final Order | 1979-10-15 |
Nr Instances | 1 |
Related Event Code (REC) | Complaint |
Citation ID | 02002 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100215 B09 |
Issuance Date | 1979-05-07 |
Abatement Due Date | 1979-05-17 |
Contest Date | 1979-06-15 |
Final Order | 1979-10-15 |
Nr Instances | 1 |
Related Event Code (REC) | Complaint |
Citation ID | 02003 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100309 A 011017 |
Issuance Date | 1979-05-07 |
Abatement Due Date | 1979-05-10 |
Contest Date | 1979-06-15 |
Final Order | 1979-10-15 |
Nr Instances | 1 |
Date of last update: 18 Mar 2025
Sources: New York Secretary of State