Name: | CROSS COUNTRY PAPER PRODUCTS CORP. |
Jurisdiction: | New York |
Legal type: | DOMESTIC BUSINESS CORPORATION |
Status: | Inactive |
Date of registration: | 16 Feb 1953 (72 years ago) |
Date of dissolution: | 30 Apr 1996 |
Entity Number: | 90714 |
ZIP code: | 10038 |
County: | Nassau |
Place of Formation: | New York |
Address: | 123 WILLIAM ST., NEW YORK, NY, United States, 10038 |
Shares Details
Shares issued 0
Share Par Value 50000
Type CAP
Name | Role | Address |
---|---|---|
% JACOB B. GERSTEN, ESQ. | DOS Process Agent | 123 WILLIAM ST., NEW YORK, NY, United States, 10038 |
Filing Number | Date Filed | Type | Effective Date |
---|---|---|---|
20051123036 | 2005-11-23 | ASSUMED NAME CORP DISCONTINUANCE | 2005-11-23 |
960429000285 | 1996-04-29 | CERTIFICATE OF MERGER | 1996-04-30 |
B191825-2 | 1985-02-11 | ASSUMED NAME CORP INITIAL FILING | 1985-02-11 |
8424-4 | 1953-02-16 | CERTIFICATE OF INCORPORATION | 1953-02-16 |
Inspection Nr | Report ID | Date Opened | Site Address | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
993873 | 0214700 | 1984-11-08 | 67 NEWMANS COURT, HEMPSTEAD, NY, 11551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11541208 | 0214700 | 1982-01-06 | 67 NEWMANS COURT, Hempstead, NY, 11551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11452703 | 0214700 | 1979-02-15 | 67 NEWMANS COURT, Hempstead, NY, 11551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11452596 | 0214700 | 1978-12-18 | 67 NEWMANS COURT, Hempstead, NY, 11551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Citation ID | 01001A |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100212 A01 |
Issuance Date | 1979-01-10 |
Abatement Due Date | 1979-03-15 |
Current Penalty | 150.0 |
Initial Penalty | 150.0 |
Nr Instances | 2 |
Citation ID | 01001B |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100212 A03 II |
Issuance Date | 1978-12-27 |
Abatement Due Date | 1979-01-30 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 01002A |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100219 D01 |
Issuance Date | 1978-12-27 |
Abatement Due Date | 1979-01-30 |
Current Penalty | 90.0 |
Initial Penalty | 90.0 |
Nr Instances | 2 |
Citation ID | 01002B |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100219 E03 I |
Issuance Date | 1978-12-27 |
Abatement Due Date | 1979-01-30 |
Nr Instances | 2 |
Citation ID | 02001 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100022 A01 |
Issuance Date | 1978-12-27 |
Abatement Due Date | 1978-12-30 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 02002 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100022 A02 |
Issuance Date | 1978-12-27 |
Abatement Due Date | 1978-12-30 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 02003 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100309 A 025045 |
Issuance Date | 1978-12-27 |
Abatement Due Date | 1978-12-30 |
Nr Instances | 1 |
Date of last update: 19 Mar 2025
Sources: New York Secretary of State