Name: | SHATSKY METAL STAMPING CO. INC. |
Jurisdiction: | New York |
Legal type: | DOMESTIC BUSINESS CORPORATION |
Status: | Inactive |
Date of registration: | 21 Feb 1955 (70 years ago) |
Date of dissolution: | 31 Jan 1983 |
Entity Number: | 96929 |
ZIP code: | 10165 |
County: | New York |
Place of Formation: | New York |
Address: | 60 E. 42ND ST., NEW YORK, NY, United States, 10165 |
Shares Details
Shares issued 200
Share Par Value 0
Type NO PAR VALUE
Name | Role | Address |
---|---|---|
%SOLOMON S. FRIEDMAN | DOS Process Agent | 60 E. 42ND ST., NEW YORK, NY, United States, 10165 |
Filing Number | Date Filed | Type | Effective Date |
---|---|---|---|
C181554-2 | 1991-10-07 | ASSUMED NAME CORP INITIAL FILING | 1991-10-07 |
A945790-5 | 1983-01-28 | CERTIFICATE OF MERGER | 1983-01-31 |
8949-58 | 1955-02-21 | CERTIFICATE OF INCORPORATION | 1955-02-21 |
Inspection Nr | Report ID | Date Opened | Site Address | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11780830 | 0215000 | 1982-01-06 | 453 GREENWICH STREET, New York -Richmond, NY, 10013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11714573 | 0215000 | 1977-05-02 | 453 GREENWICH ST, New York -Richmond, NY, 10013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11714342 | 0215000 | 1977-03-31 | 453 GREENWICH ST, New York -Richmond, NY, 10013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Citation ID | 01001 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100217 C02 IA |
Issuance Date | 1977-04-12 |
Abatement Due Date | 1977-04-18 |
Current Penalty | 420.0 |
Initial Penalty | 420.0 |
Nr Instances | 6 |
Citation ID | 02001 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100217 E01 I |
Issuance Date | 1977-04-12 |
Abatement Due Date | 1977-04-26 |
Nr Instances | 11 |
Citation ID | 02002 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100217 E01 II |
Issuance Date | 1977-04-12 |
Abatement Due Date | 1977-04-26 |
Nr Instances | 9 |
Citation ID | 02003 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100037 Q01 |
Issuance Date | 1977-04-12 |
Abatement Due Date | 1977-04-18 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 02004 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100037 Q05 |
Issuance Date | 1977-04-12 |
Abatement Due Date | 1977-04-20 |
Nr Instances | 2 |
Citation ID | 02005 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100157 A05 |
Issuance Date | 1977-04-12 |
Abatement Due Date | 1977-04-19 |
Nr Instances | 3 |
Citation ID | 02006 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100157 A03 |
Issuance Date | 1977-04-12 |
Abatement Due Date | 1977-04-20 |
Nr Instances | 3 |
Citation ID | 02007 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19040002 A |
Issuance Date | 1977-04-12 |
Abatement Due Date | 1977-04-19 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 02008 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19040005 A |
Issuance Date | 1977-04-12 |
Abatement Due Date | 1977-04-15 |
Nr Instances | 1 |
Date of last update: 19 Mar 2025
Sources: New York Secretary of State